-
PETROW ESTATES LIMITED - The Coach House, 61c Guildford Street, Chertsey, KT16 9AU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06555193
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Coach House
- 61c Guildford Street
- Chertsey
- KT16 9AU
- England The Coach House, 61c Guildford Street, Chertsey, KT16 9AU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WILLINGALE, Myles Lee
- WILLINGALE, Roger
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.04.2008
- Alter der Firma 2008-04-04 16 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Roger Willingale
- Mr Myles Lee Willingale
- Mrs Carol Willingale
- Mrs Carol Willingale
- Mr Roger Willingale
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-01-31
- Letzte Einreichung: 2021-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-18
- Letzte Einreichung: 2021-04-04
-
PETROW ESTATES LIMITED Firmenbeschreibung
- PETROW ESTATES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06555193. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.04.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.04.2012.Die Firma kann schriftlich über The Coach House erreicht werden.
Jetzt sichern PETROW ESTATES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Petrow Estates Limited - The Coach House, 61c Guildford Street, Chertsey, KT16 9AU, Grossbritannien
- 2008-04-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PETROW ESTATES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-01-20) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-01-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-20) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-01-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-21) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-12) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-01) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-05) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-04-10) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-10) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-10) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-11-08) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-11-08) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-13) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-23) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-10) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-07) - AP01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-10-07) - DISS40
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-10-06) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-06) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-10-06) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-06) - AD01
-
gazette-notice-compulsary (2014-08-05) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-02-02) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-28) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-04-27) - 363a
-
legacy (2009-04-27) - 288c
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-01) - 88(2)
-
legacy (2008-09-01) - 287
-
legacy (2008-04-15) - 287
-
resolution (2008-04-10) - RESOLUTIONS
-
legacy (2008-04-08) - 288a
-
legacy (2008-04-08) - 288b
-
incorporation-company (2008-04-04) - NEWINC