-
RACING AHEAD WEEKEND LIMITED - New Chartford House, Centurion Way, Cleckheaton, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06548254
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- New Chartford House
- Centurion Way
- Cleckheaton
- West Yorkshire
- BD19 3QB New Chartford House, Centurion Way, Cleckheaton, West Yorkshire, BD19 3QB UK
Management
- Geschäftsführung
- POWER, Lee Michael
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.03.2008
- Alter der Firma 2008-03-28 16 Jahre
- SIC/NACE
- 58130
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Lee Michael Power
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-12-31
- Letzte Einreichung: 2017-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-03-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-04-11
- Letzte Einreichung: 2018-03-28
-
RACING AHEAD WEEKEND LIMITED Firmenbeschreibung
- RACING AHEAD WEEKEND LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06548254. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.03.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58130" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2017 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.03.2014.Die Firma kann schriftlich über New Chartford House erreicht werden.
Jetzt sichern RACING AHEAD WEEKEND LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Racing Ahead Weekend Limited - New Chartford House, Centurion Way, Cleckheaton, West Yorkshire, Grossbritannien
- 2008-03-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RACING AHEAD WEEKEND LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2021-01-20) - WU07
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2020-01-11) - WU07
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-miscellaneous (2019-11-20) - LIQ MISC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-31) - AD01
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2019-01-17) - WU04
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2019-11-20) - COCOMP
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2018-07-27) - COCOMP
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-23) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-01) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-27) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-05) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-06-24) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-06-13) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-05) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
gazette-notice-compulsory (2015-04-14) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-31) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-08-15) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-13) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2015-08-11) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-05-16) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-15) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-13) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-25) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-03-12) - TM01
-
capital-allotment-shares (2013-03-12) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-09) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-05-02) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-19) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
gazette-notice-compulsary (2011-04-05) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-04-09) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-10) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-05-16) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-06-15) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-01) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-11-01) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-02-09) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-11-23) - AD01
-
legacy (2009-06-30) - 288b
-
legacy (2009-06-05) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-03-28) - NEWINC