-
BRAEBURN PROJECTS LIMITED - BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP, Cathedral Buildings Dean Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 1PG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06543868
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
- Cathedral Buildings Dean Street
- Newcastle Upon Tyne
- NE1 1PG BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP, Cathedral Buildings Dean Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 1PG UK
Management
- Geschäftsführung
- GRIEVSON, Jane
- GRIEVSON, Richard James
- Prokuristen
- GRIEVSON, Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.03.2008
- Gelöscht am:
- 2021-04-12
- SIC/NACE
- 68100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- SOUTHERN PROPERTIES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-12-31
- Letzte Einreichung: 2015-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-03-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-04-09
- Letzte Einreichung:
-
BRAEBURN PROJECTS LIMITED Firmenbeschreibung
- BRAEBURN PROJECTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06543868. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 26.03.2008 registriert. BRAEBURN PROJECTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SOUTHERN PROPERTIES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2015 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.03.2015.Die Firma kann schriftlich über Begbies Traynor (Central) Llp erreicht werden.
Jetzt sichern BRAEBURN PROJECTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Braeburn Projects Limited - BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP, Cathedral Buildings Dean Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 1PG, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRAEBURN PROJECTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
resolution (2020-08-18) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-21) - LIQ03
-
change-of-name-notice (2020-08-18) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-05-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-06-12) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-05-26) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-31) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2016-03-30) - 4.70
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-03-30) - 600
-
resolution (2016-03-30) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-04) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-12-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-04-22) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
certificate-change-of-name-company (2008-09-30) - CERTNM
-
incorporation-company (2008-03-26) - NEWINC