-
NICKALLS & CO LTD. - 4 Bridge Street, Amble, Morpeth, Northumberland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06521674
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 Bridge Street
- Amble
- Morpeth
- Northumberland
- NE65 0DR 4 Bridge Street, Amble, Morpeth, Northumberland, NE65 0DR UK
Management
- Geschäftsführung
- GRAHAMSLAW, Patricia Jane
- NICKALLS, Derek Gibson Sproat
- Prokuristen
- GRAHAMSLAW, Patricia Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.03.2008
- Alter der Firma 2008-03-03 16 Jahre
- SIC/NACE
- 69201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Patricia Jane Grahamslaw
- Ms Patricia Jane Grahamslaw
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-02-28
- Letzte Einreichung: 2021-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-03
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-04-15
- Letzte Einreichung: 2022-04-01
-
NICKALLS & CO LTD. Firmenbeschreibung
- NICKALLS & CO LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06521674. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.03.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69201" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 4 Bridge Street erreicht werden.
Jetzt sichern NICKALLS & CO LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nickalls & Co Ltd. - 4 Bridge Street, Amble, Morpeth, Northumberland, Grossbritannien
- 2008-03-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NICKALLS & CO LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-06-13) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2023-05-02) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2022
-
gazette-notice-compulsory (2022-06-21) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-03-31) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-06-22) - DISS40
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-15) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-12-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-01-02) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-17) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-17) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-07-17) - CH03
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-14) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-05-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-31) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-26) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-25) - AA
-
change-sail-address-company (2010-03-08) - AD02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-31) - AA
-
move-registers-to-sail-company (2010-03-08) - AD03
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-10) - 363a
-
legacy (2009-03-10) - 288c
-
legacy (2009-03-10) - 288a
keyboard_arrow_right 2008
-
statement-of-affairs (2008-04-24) - SA
-
legacy (2008-04-24) - 88(2)
-
incorporation-company (2008-03-03) - NEWINC