-
UNTANGLED PRINT SOLUTIONS LIMITED - Leigh House, 28-32 St Paul's Street, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06496847
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Leigh House
- 28-32 St Paul's Street
- Leeds
- West Yorkshire
- LS1 2JT Leigh House, 28-32 St Paul's Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 2JT UK
Management
- Geschäftsführung
- GILL, Anthony Stephen
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.02.2008
- Gelöscht am:
- 2021-07-06
- SIC/NACE
- 18130
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mosaic Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- FACE DM LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-04-30
- Letzte Einreichung: 2020-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-21
- Letzte Einreichung: 2021-02-07
-
UNTANGLED PRINT SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- UNTANGLED PRINT SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06496847. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 07.02.2008 registriert. UNTANGLED PRINT SOLUTIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FACE DM LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "18130" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Leigh House erreicht werden.
Jetzt sichern UNTANGLED PRINT SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Untangled Print Solutions Limited - Leigh House, 28-32 St Paul's Street, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu UNTANGLED PRINT SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-voluntary (2021-04-20) - GAZ1(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-10) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-04-13) - DS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-04-12) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-03-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-02-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-21) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-21) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-02-20) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-03-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-02-15) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-04-15) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-18) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-23) - MR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-12-18) - TM02
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-04-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-10-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-03-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-02-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-05-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-04-20) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-03) - AR01
-
memorandum-articles (2011-01-07) - MEM/ARTS
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-25) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-26) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-07-28) - AA01
-
resolution (2010-10-21) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-04-21) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2010-10-21) - SH08
-
capital-allotment-shares (2010-10-21) - SH01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-10-28) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-10-28) - AP03
-
statement-of-companys-objects (2010-10-21) - CC04
keyboard_arrow_right 2009
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-11-26) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-11-20) - AA
-
termination-director-company-with-name (2009-10-25) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2009-10-24) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2009-10-24) - CONNOT
-
memorandum-articles (2009-07-04) - MEM/ARTS
-
certificate-change-of-name-company (2009-06-12) - CERTNM
-
legacy (2009-03-02) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-02-07) - NEWINC