-
TYTHERLEIGH HOMES LTD - Hook Mills, Chardstock, Axminster, Devon, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06495528
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hook Mills
- Chardstock
- Axminster
- Devon
- EX13 7DD
- England Hook Mills, Chardstock, Axminster, Devon, EX13 7DD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- JAMES, Steven John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.02.2008
- Alter der Firma 2008-02-06 16 Jahre
- SIC/NACE
- 42990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Steven John James
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-20
- Letzte Einreichung: 2023-02-06
-
TYTHERLEIGH HOMES LTD Firmenbeschreibung
- TYTHERLEIGH HOMES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06495528. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.02.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "42990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Hook Mills erreicht werden.
Jetzt sichern TYTHERLEIGH HOMES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tytherleigh Homes Ltd - Hook Mills, Chardstock, Axminster, Devon, Grossbritannien
- 2008-02-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TYTHERLEIGH HOMES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-04-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-03-10) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-03-11) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-03-11) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-11-29) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-14) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-04-01) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-06-14) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-14) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-19) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-06) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-06) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-05-10) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-07) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-09) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-02-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-12) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2009-11-11) - AA01
-
legacy (2009-02-16) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-02-06) - NEWINC