-
GLOBUS MEDICAL UK LTD - Heathrow Boulevard 2 284 Bath Road, Sipson, West Drayton, UB7 0DQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06491893
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Heathrow Boulevard 2 284 Bath Road
- Sipson
- West Drayton
- UB7 0DQ
- England Heathrow Boulevard 2 284 Bath Road, Sipson, West Drayton, UB7 0DQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- PFEIL, Keith
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.02.2008
- Alter der Firma 2008-02-04 16 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Keith Pfeil
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-13
- Letzte Einreichung: 2020-01-30
-
GLOBUS MEDICAL UK LTD Firmenbeschreibung
- GLOBUS MEDICAL UK LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06491893. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.02.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Heathrow Boulevard 2 284 Bath Road erreicht werden.
Jetzt sichern GLOBUS MEDICAL UK LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Globus Medical Uk Ltd - Heathrow Boulevard 2 284 Bath Road, Sipson, West Drayton, UB7 0DQ, Grossbritannien
- 2008-02-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GLOBUS MEDICAL UK LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-13) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-01-31) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-01-31) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-31) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-16) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-04) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-18) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-10) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-27) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-03-27) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2013-03-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-29) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-27) - AA
-
resolution (2011-06-07) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-06-16) - AD01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2011-06-07) - SH19
-
legacy (2011-06-07) - SH20
-
legacy (2011-06-07) - CAP-SS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-secretary-company-with-name (2010-01-12) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-02-10) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-12-29) - AP01
-
capital-allotment-shares (2010-10-11) - SH01
keyboard_arrow_right 2009
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-11-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-02-24) - AA
-
legacy (2009-02-20) - 363a
-
legacy (2009-01-29) - 225
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-02-04) - NEWINC
-
legacy (2008-04-23) - 395
-
legacy (2008-03-04) - 288b
-
legacy (2008-02-29) - 288a