-
BLACKBOURNE DEVELOPMENTS LTD - 22 Friars Street, Sudbury, Suffolk, CO10 2AA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06473270
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 22 Friars Street
- Sudbury
- Suffolk
- CO10 2AA 22 Friars Street, Sudbury, Suffolk, CO10 2AA UK
Management
- Geschäftsführung
- DRISCOLL, Daniel Patrick
- DRISCOLL, Susanne Mary
- Prokuristen
- DRISCOLL, Susanne Mary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.01.2008
- Alter der Firma 2008-01-15 16 Jahre
- SIC/NACE
- 41202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Daniel Patrick Driscoll
- Susanne Mary Driscoll
- Daniel Patrick Driscoll
- Susanne Mary Driscoll
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-10-31
- Letzte Einreichung: 2022-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-26
- Letzte Einreichung: 2023-02-12
-
BLACKBOURNE DEVELOPMENTS LTD Firmenbeschreibung
- BLACKBOURNE DEVELOPMENTS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06473270. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.01.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41202" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 22 Friars Street erreicht werden.
Jetzt sichern BLACKBOURNE DEVELOPMENTS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Blackbourne Developments Ltd - 22 Friars Street, Sudbury, Suffolk, CO10 2AA, Grossbritannien
- 2008-01-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLACKBOURNE DEVELOPMENTS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-05) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-03-30) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-24) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-02-13) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-22) - CS01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2019-01-15) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-01-15) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-09-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-13) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-16) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-07-27) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-22) - AA
-
legacy (2013-03-19) - MG01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-20) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-11) - AA
-
legacy (2012-03-24) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date (2012-02-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date (2011-01-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-04) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2009-10-28) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-10-28) - CH01
-
legacy (2009-02-26) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-06) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-01-15) - NEWINC