-
JANSEN DISPLAY LTD - Unit 20,, The Courtyard, Greenewable Park Station Lane, Offord Cluny, St. Neots, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06458734
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 20,
- The Courtyard, Greenewable Park Station Lane
- Offord Cluny
- St. Neots
- PE19 5ZA
- England Unit 20,, The Courtyard, Greenewable Park Station Lane, Offord Cluny, St. Neots, PE19 5ZA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ZAJICEK, Vit
- Prokuristen
- CASTON, Leslie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.12.2007
- Gelöscht am:
- 2021-01-26
- SIC/NACE
- 46900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Pfingsten Partners Fund V
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-01-03
- Letzte Einreichung: 2018-12-20
-
JANSEN DISPLAY LTD Firmenbeschreibung
- JANSEN DISPLAY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06458734. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.12.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46900" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 20 erreicht werden.
Jetzt sichern JANSEN DISPLAY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jansen Display Ltd - Unit 20,, The Courtyard, Greenewable Park Station Lane, Offord Cluny, St. Neots, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JANSEN DISPLAY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-26) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-07-16) - AP03
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-10-19) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-10-19) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-08-11) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-17) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-05-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-04-05) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-02-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-02-02) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-08-19) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-14) - AD01
-
capital-allotment-shares (2010-04-27) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-10-26) - AP01
-
legacy (2010-11-17) - MG01
-
accounts-amended-with-made-up-date (2010-10-25) - AAMD
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2009-04-02) - AA
-
legacy (2009-02-06) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-02-20) - 288a
-
legacy (2008-01-03) - 288b
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-12-20) - NEWINC