-
118777 LIMITED - 2 Hardman Street, Manchester, M3 3HF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06434523
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Hardman Street
- Manchester
- M3 3HF 2 Hardman Street, Manchester, M3 3HF UK
Management
- Geschäftsführung
- DOHERTY, Paul Nicholas
- Prokuristen
- HILL, Gillian Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.11.2007
- Alter der Firma 2007-11-22 16 Jahre
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Verastar Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-01-31
- Letzte Einreichung: 2017-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-12-04
- Letzte Einreichung: 2018-11-20
-
118777 LIMITED Firmenbeschreibung
- 118777 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06434523. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.11.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.11.2012.Die Firma kann schriftlich über 2 Hardman Street erreicht werden.
Jetzt sichern 118777 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 118777 Limited - 2 Hardman Street, Manchester, M3 3HF, Grossbritannien
- 2007-11-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 118777 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2021-05-05) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-04) - TM01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-09-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-09-19) - 600
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-09-09) - LIQ01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-27) - AD01
-
resolution (2019-08-25) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-06-05) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-02-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-02-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-26) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-19) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-03) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-12-03) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-12-03) - TM02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-10-27) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-20) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-02-04) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-09-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-17) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-03-12) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2013-03-07) - TM02
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-07-24) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-22) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-09-06) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-20) - AP01
-
legacy (2011-05-09) - MG01
-
resolution (2011-05-03) - RESOLUTIONS
-
statement-of-companys-objects (2011-05-03) - CC04
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-10-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-09) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2009-12-09) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-full (2009-10-21) - AA
-
accounts-with-accounts-type-full (2009-03-03) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-27) - 363a
-
legacy (2008-07-02) - 288b
-
legacy (2008-07-02) - 288a
-
legacy (2008-03-31) - 225
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-11-22) - NEWINC