-
THE OVEN DOOR BAKERY LIMITED - Suite A 7th Floor City Gate East, Tollhouse Hill, Nottingham, NG1 5FS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06415863
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite A 7th Floor City Gate East
- Tollhouse Hill
- Nottingham
- NG1 5FS Suite A 7th Floor City Gate East, Tollhouse Hill, Nottingham, NG1 5FS UK
Management
- Geschäftsführung
- GOULD, Nicholas Andrew
- Prokuristen
- FORSTER, Anthony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.11.2007
- Gelöscht am:
- 2021-07-30
- SIC/NACE
- 47240
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-08-31
- Letzte Einreichung: 2015-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-11-03
- Letzte Einreichung: 2016-10-20
-
THE OVEN DOOR BAKERY LIMITED Firmenbeschreibung
- THE OVEN DOOR BAKERY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06415863. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 02.11.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47240" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2015 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Suite A 7Th Floor City Gate East erreicht werden.
Jetzt sichern THE OVEN DOOR BAKERY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Oven Door Bakery Limited - Suite A 7th Floor City Gate East, Tollhouse Hill, Nottingham, NG1 5FS, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE OVEN DOOR BAKERY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-07-30) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-04-30) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-03-02) - 600
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2020-02-20) - AM22
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-06-04) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-06-04) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-03-08) - AM10
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-09-09) - AM10
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2018-12-13) - AM19
-
liquidation-in-administration-progress-report (2018-09-11) - AM10
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2018-05-04) - AM06
-
liquidation-in-administration-proposals (2018-04-29) - AM03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-07) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-03-06) - AM01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-09-06) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-10) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-10) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-06-10) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-06-22) - AP03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-06-14) - MR01
-
resolution (2016-06-21) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-27) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-10) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-25) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-06) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-27) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-10-14) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-31) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-10-14) - CH03
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-04) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-11-02) - NEWINC