-
D & C SOUND AND VISION LIMITED - Crown House, 217 Higher Hillgate, Stockport, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06409378
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Crown House
- 217 Higher Hillgate
- Stockport
- Cheshire
- SK1 3RB Crown House, 217 Higher Hillgate, Stockport, Cheshire, SK1 3RB UK
Management
- Geschäftsführung
- GILMAN, Iain Thomas
- GILMAN, Sarah Ann
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.10.2007
- Alter der Firma 2007-10-25 16 Jahre
- SIC/NACE
- 47430
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Iain Thomas Gilman
- Mrs Sarah Ann Gilman
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-05-01
- Letzte Einreichung: 2019-04-17
-
D & C SOUND AND VISION LIMITED Firmenbeschreibung
- D & C SOUND AND VISION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06409378. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.10.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47430" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Crown House erreicht werden.
Jetzt sichern D & C SOUND AND VISION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: D & C Sound And Vision Limited - Crown House, 217 Higher Hillgate, Stockport, Cheshire, Grossbritannien
- 2007-10-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu D & C SOUND AND VISION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-11-05) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-17) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-17) - CS01
-
resolution (2019-09-13) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-09-25) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-16) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-09-13) - 600
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-02) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-23) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-13) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-02-13) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-02) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-25) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-10-25) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-14) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-26) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-11-26) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-11-25) - CH03
-
termination-secretary-company-with-name (2010-11-25) - TM02
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-11-25) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-18) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-06) - AA
-
legacy (2009-02-12) - 287
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-01-17) - 288a
-
legacy (2008-07-22) - 288b
-
legacy (2008-12-02) - 288c
-
legacy (2008-12-11) - 288c
-
legacy (2008-12-11) - 363a
-
legacy (2008-12-16) - 288c
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-12-06) - 88(2)R
-
legacy (2007-11-09) - 288a
-
legacy (2007-11-09) - 287
-
incorporation-company (2007-10-25) - NEWINC