-
SYNTEGRA CONSULTING LTD - 63 Milford Road, Reading, RG1 8LG, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06408056
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 63 Milford Road
- Reading
- RG1 8LG
- England 63 Milford Road, Reading, RG1 8LG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LAWTHER, Samuel David
- WING-KING, Alan Raymond
- WING-KING, Jane
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.10.2007
- Alter der Firma 2007-10-24 16 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Alan Raymond Wing-King
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-24
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-05
- Letzte Einreichung: 2019-10-24
-
SYNTEGRA CONSULTING LTD Firmenbeschreibung
- SYNTEGRA CONSULTING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06408056. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.10.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 24.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 63 Milford Road erreicht werden.
Jetzt sichern SYNTEGRA CONSULTING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Syntegra Consulting Ltd - 63 Milford Road, Reading, RG1 8LG, England, Grossbritannien
- 2007-10-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SYNTEGRA CONSULTING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-03) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-09-27) - SH08
-
capital-allotment-shares (2019-09-27) - SH01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2019-09-27) - SH10
-
resolution (2019-09-30) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2019-09-30) - MA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-27) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-08-30) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-07) - CS01
-
capital-allotment-shares (2017-09-05) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-20) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-08-14) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-09) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-01-09) - CH03
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-07-22) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-10) - MR01
-
change-person-director-company (2013-07-22) - CH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-07-22) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-01) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-19) - MR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-02-03) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-09-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-02-22) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-11-07) - AA
-
legacy (2008-11-06) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-10-24) - NEWINC