-
DEMINOS LTD - Bulman House Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 3LS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06376910
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bulman House Regent Centre
- Gosforth
- Newcastle Upon Tyne
- NE3 3LS Bulman House Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 3LS UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.09.2007
- Alter der Firma 2007-09-20 16 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Neil Atkinson
- Mrs Louise Atkinson
- Mr Neil Atkinson
- Mrs Louise Atkinson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-03-31
- Letzte Einreichung: 2015-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-10-04
- Letzte Einreichung: 2016-09-20
-
DEMINOS LTD Firmenbeschreibung
- DEMINOS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06376910. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.09.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 28/02/2012 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Bulman House Regent Centre erreicht werden.
Jetzt sichern DEMINOS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Deminos Ltd - Bulman House Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 3LS, Grossbritannien
- 2007-09-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DEMINOS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-08-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-12-20) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-20) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-19) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-08-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2018-06-14) - AM07
-
liquidation-in-administration-progress-report (2018-06-05) - AM10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-07-04) - 600
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2018-06-15) - AM22
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2017-06-19) - AM01
-
liquidation-in-administration-proposals (2017-08-08) - AM03
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-03-25) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-20) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-11-19) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-24) - TM01
-
capital-allotment-shares (2015-05-07) - SH01
-
statement-of-companys-objects (2015-03-25) - CC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-15) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-12) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-08-07) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-08) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-06) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-27) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-11-11) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-17) - AA
-
legacy (2009-07-13) - 225
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-26) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-26) - 287
-
incorporation-company (2007-09-20) - NEWINC