-
PENDLE VEHICLE CONTRACTS LIMITED - Juniper House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06361003
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Juniper House Warley Hill Business Park
- The Drive
- Brentwood
- Essex
- CM13 3BE
- England Juniper House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, CM13 3BE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- THORNE, Tony
- Prokuristen
- CANNELL, Nancy Julie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.09.2007
- Alter der Firma 2007-09-04 16 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Tony Thorne
- Mrs Nancy Julie Cannell
- Mr Tony Thorne
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-18
- Letzte Einreichung: 2023-09-04
-
PENDLE VEHICLE CONTRACTS LIMITED Firmenbeschreibung
- PENDLE VEHICLE CONTRACTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06361003. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.09.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Juniper House Warley Hill Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern PENDLE VEHICLE CONTRACTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pendle Vehicle Contracts Limited - Juniper House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien
- 2007-09-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PENDLE VEHICLE CONTRACTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-09-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-08-09) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-02) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-09-12) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-09-12) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-26) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-04-06) - CH03
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-12) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-21) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-24) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-03) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-02) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-01-03) - TM01
-
capital-allotment-shares (2012-06-22) - SH01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-23) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-02) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-02-02) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2011-02-02) - TM02
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-28) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-28) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-08-12) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2010-11-23) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-11) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-24) - AA
-
legacy (2009-01-21) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-09-04) - NEWINC
-
legacy (2007-09-23) - 288a
-
legacy (2007-09-07) - 288b