-
SWEETS GALORE LIMITED - Trinity House, 28-30 Blucher Street, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06314071
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Trinity House
- 28-30 Blucher Street
- Birmingham
- West Midlands
- B1 1QH Trinity House, 28-30 Blucher Street, Birmingham, West Midlands, B1 1QH UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- MCCULLOCH, Anne Judith
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.07.2007
- Gelöscht am:
- 2021-09-17
- SIC/NACE
- 47240
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Anne Judith Mcculloch
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-12-31
- Letzte Einreichung: 2016-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-07-30
- Letzte Einreichung: 2017-07-16
-
SWEETS GALORE LIMITED Firmenbeschreibung
- SWEETS GALORE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06314071. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 16.07.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47240" registriert. und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Trinity House erreicht werden.
Jetzt sichern SWEETS GALORE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sweets Galore Limited - Trinity House, 28-30 Blucher Street, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SWEETS GALORE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-06-17) - LIQ14
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-09-17) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-09-05) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-05-30) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-09-05) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-05-02) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-05-02) - 600
-
resolution (2019-05-02) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-04-28) - DISS40
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-04-14) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-04-27) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-04-27) - CH03
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-11) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-11-12) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2016-10-11) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-14) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-14) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-01-14) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2014-04-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-14) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-30) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-04-01) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2014-01-14) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-14) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-29) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-07-29) - CH03
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-18) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-04-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-10-10) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-04-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-04-22) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-08-05) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-08-18) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-08-11) - AA
-
legacy (2008-07-22) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
resolution (2007-07-31) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2007-07-16) - NEWINC