-
DRIVE SYSTEM DESIGN LIMITED - Unit B, Berrington Road, Leamington Spa, Warwickshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06304697
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit B
- Berrington Road
- Leamington Spa
- Warwickshire
- CV31 1NB Unit B, Berrington Road, Leamington Spa, Warwickshire, CV31 1NB UK
Management
- Geschäftsführung
- ANDREWS, Gerald Anthony
- FINDLAY, Elizabeth Liilian Catherine
- FINDLAY, Mark Edward
- KELLY, David Francis
- KELLY, Samantha Jane
- MORTON, John David
- MORTON, Susan
- TYLEE-BIRDSALL, Alexander James
- TYLEE-BIRDSALL, Rebecca Louise
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.07.2007
- Alter der Firma 2007-07-06 16 Jahre
- SIC/NACE
- 72190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Alexander James Tylee-Birdsall
- Mr Mark Edward Findlay
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2017-07-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-12
- Letzte Einreichung: 2020-06-28
-
DRIVE SYSTEM DESIGN LIMITED Firmenbeschreibung
- DRIVE SYSTEM DESIGN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06304697. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.07.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "72190" registriert. Das Unternehmen hat 9 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.07.2017.Die Firma kann schriftlich über Unit B erreicht werden.
Jetzt sichern DRIVE SYSTEM DESIGN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Drive System Design Limited - Unit B, Berrington Road, Leamington Spa, Warwickshire, Grossbritannien
- 2007-07-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DRIVE SYSTEM DESIGN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-06) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-03-15) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-15) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-10-01) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-28) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-06-28) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-05-18) - CH03
-
resolution (2017-11-21) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-11-14) - SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-07-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-15) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-07-15) - CH03
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2014-07-15) - AD02
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-15) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-03) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-10) - AR01
-
move-registers-to-registered-office-company (2013-07-10) - AD04
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-09-26) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-02) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2011-01-17) - SH08
-
resolution (2011-01-17) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2010
-
change-sail-address-company (2010-08-02) - AD02
-
move-registers-to-sail-company (2010-08-02) - AD03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
capital-allotment-shares (2009-12-29) - SH01
-
legacy (2009-07-31) - 363a
-
legacy (2009-06-23) - 288a
-
legacy (2009-06-16) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-05-09) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-28) - 363a
-
legacy (2008-05-09) - 225
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-07-06) - NEWINC