-
FERNDALE PRODUCE LIMITED - MARSHALL PETERS, Heskin Hall Farm Wood Lane, Heskin, Preston, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06236608
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- MARSHALL PETERS
- Heskin Hall Farm Wood Lane
- Heskin
- Preston
- PR7 5PA MARSHALL PETERS, Heskin Hall Farm Wood Lane, Heskin, Preston, PR7 5PA UK
Management
- Geschäftsführung
- AUGHTON, Ann
- AUGHTON, Daniel Peter
- AUGHTON, Philip John
- Prokuristen
- AUGHTON, Philip John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.05.2007
- Alter der Firma 2007-05-03 17 Jahre
- SIC/NACE
- 01130
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Philip John Aughton
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-05-17
- Letzte Einreichung: 2019-05-03
-
FERNDALE PRODUCE LIMITED Firmenbeschreibung
- FERNDALE PRODUCE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06236608. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.05.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "01130" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Marshall Peters erreicht werden.
Jetzt sichern FERNDALE PRODUCE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ferndale Produce Limited - MARSHALL PETERS, Heskin Hall Farm Wood Lane, Heskin, Preston, Grossbritannien
- 2007-05-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FERNDALE PRODUCE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-11-05) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-05-28) - LIQ02
-
resolution (2020-05-28) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-02) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-05-28) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-11) - CS01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2018-05-11) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2018-05-11) - AD02
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-31) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-05) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-03) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-31) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-18) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-18) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-30) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-28) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-01-10) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-01-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-02) - AR01
-
legacy (2011-04-19) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-05-25) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-20) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-11-03) - AA
-
legacy (2009-06-03) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-04-06) - AA
-
legacy (2009-04-02) - 225
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-30) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-02) - 288a
-
legacy (2007-06-18) - 288b
-
incorporation-company (2007-05-03) - NEWINC