-
EU ECO HUB CIC - 21 St. Annes Crescent, Lewes, BN7 1SB, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06218952
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 21 St. Annes Crescent
- Lewes
- BN7 1SB
- England 21 St. Annes Crescent, Lewes, BN7 1SB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- TURNER, Charlie Norman
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.04.2007
- Gelöscht am:
- 2014-07-15
- SIC/NACE
- 88990
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Ehemalige Namen
- CARE CO-OPERATIVES COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICE CIC
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-16
- Letzte Einreichung: 2023-02-02
-
EU ECO HUB CIC Firmenbeschreibung
- EU ECO HUB CIC ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06218952. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.04.2007 registriert. EU ECO HUB CIC hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CARE CO-OPERATIVES COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICE CIC ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "88990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.04.2012.Die Firma kann schriftlich über 21 St. Annes Crescent erreicht werden.
Jetzt sichern EU ECO HUB CIC HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Eu Eco Hub Cic - 21 St. Annes Crescent, Lewes, BN7 1SB, England, Grossbritannien
- 2007-04-19
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EU ECO HUB CIC aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-notice-compulsory (2024-03-12) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2024-04-16) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-12-29) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-28) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-07-06) - TM02
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-06-05) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-04) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2020-03-03) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-04-15) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-04) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-17) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-06-09) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-06) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-05-22) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-02-15) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-of-name-notice (2017-01-11) - CONNOT
-
resolution (2017-01-11) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-28) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-of-name-notice (2016-12-29) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-03-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-14) - AR01
-
administrative-restoration-company (2016-03-14) - RT01
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-dissolved-compulsary (2014-07-15) - GAZ2
-
gazette-notice-compulsary (2014-04-01) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-04-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-11-05) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-11) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-10-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-06-02) - AA
-
legacy (2009-04-21) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-04-22) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-05-21) - 225
-
legacy (2007-05-03) - 288b
-
incorporation-community-interest-company (2007-04-19) - CICINC