-
DEANEM COLLECTIONS LIMITED - 3rd, Floor 37 Frederick Place, Brighton, BN1 4EA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06209331
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd
- Floor 37 Frederick Place
- Brighton
- BN1 4EA 3rd, Floor 37 Frederick Place, Brighton, BN1 4EA UK
Management
- Geschäftsführung
- BAUM, David Joseph
- BAUM, Melanie Jane
- Prokuristen
- BAUM, Philip Alex
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.04.2007
- Gelöscht am:
- 2020-03-20
- SIC/NACE
- 64999
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-12-31
- Letzte Einreichung: 2015-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-31
-
DEANEM COLLECTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- DEANEM COLLECTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06209331. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.04.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 3Rd erreicht werden.
Jetzt sichern DEANEM COLLECTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Deanem Collections Limited - 3rd, Floor 37 Frederick Place, Brighton, BN1 4EA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DEANEM COLLECTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-03-20) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-02-25) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2019-12-20) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-02-02) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2017-08-24) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-08-24) - 600
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-05-12) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-14) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-07) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-12-13) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-21) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-12-30) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-12-30) - 4.20
-
resolution (2016-12-30) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-28) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-06-15) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-10) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-03-28) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-06-10) - CH01
-
accounts-amended-with-made-up-date (2013-12-18) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-29) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-06-10) - CH03
-
legacy (2013-03-12) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-20) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-09-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-03) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-03-08) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-03-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-30) - AA
-
legacy (2011-11-25) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-26) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-05-26) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-12) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-01) - AA
-
legacy (2009-05-01) - 363a
-
legacy (2009-04-06) - 288a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-08-19) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-08-14) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-05-02) - 288b
-
legacy (2007-05-02) - 288a
-
legacy (2007-04-29) - 225
-
incorporation-company (2007-04-11) - NEWINC