-
ENTERPRISE FACTORIES LIMITED - Tickton Hall, Tickton, Beverley, HU17 9RX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06172823
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Tickton Hall
- Tickton
- Beverley
- HU17 9RX
- England Tickton Hall, Tickton, Beverley, HU17 9RX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FOREMAN, Andrew Patrick
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.03.2007
- Alter der Firma 2007-03-20 17 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Eco Modular Manufacturing Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- FOREMANS ENTERPRISE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-01
- Letzte Einreichung: 2020-03-20
-
ENTERPRISE FACTORIES LIMITED Firmenbeschreibung
- ENTERPRISE FACTORIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06172823. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.03.2007 registriert. ENTERPRISE FACTORIES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FOREMANS ENTERPRISE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Tickton Hall erreicht werden.
Jetzt sichern ENTERPRISE FACTORIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Enterprise Factories Limited - Tickton Hall, Tickton, Beverley, HU17 9RX, Grossbritannien
- 2007-03-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ENTERPRISE FACTORIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-08-25) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-01) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-25) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-25) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-07-23) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2014-07-22) - GAZ1
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-06-18) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-12-10) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-06-19) - MR04
-
certificate-change-of-name-company (2013-06-07) - CERTNM
-
resolution (2013-06-03) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-31) - AR01
-
liquidation-voluntary-arrangement-completion (2013-05-24) - 1.4
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-05-21) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-05-16) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-26) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2012-08-24) - 1.3
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2011-08-09) - 1.1
-
legacy (2011-07-21) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-20) - AR01
-
accounts-amended-with-made-up-date (2011-04-18) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-02-18) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-16) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-02-18) - TM02
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2010-12-10) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-11-01) - TM02
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-12-23) - AA
-
legacy (2009-04-06) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-02-20) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-04-16) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-01) - 395
-
legacy (2007-10-15) - 288a
-
legacy (2007-10-15) - 288b
-
legacy (2007-05-02) - 288a
-
legacy (2007-04-19) - 288b
-
legacy (2007-04-19) - 288a
-
incorporation-company (2007-03-20) - NEWINC