-
PICASSO PICTURES LIMITED - 6th Floor Charlotte Building, 17 Gresse Street, London, W1T 1QL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06157859
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 6th Floor Charlotte Building
- 17 Gresse Street
- London
- W1T 1QL
- United Kingdom 6th Floor Charlotte Building, 17 Gresse Street, London, W1T 1QL, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- PRICE, Richard John Douglas
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.03.2007
- Alter der Firma 2007-03-13 17 Jahre
- SIC/NACE
- 59111
Eigentumsverhältnisse
- Anteilseigner
- MRS SOPHIE MARIE GAUDIN (30.00%)
- MR RICHARD JOHN DOUGLAS PRICE (70.00%)
- Beneficial Owners
- Mr Richard John Douglas Price
- Mrs Sophie Marie Price
Landes-Besonderheiten
- Firmenname (in Englisch)
- Picasso Pictures Limited
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- JB&RP LIMITED
- UID/USt-ID-Nummer
- GB906221457
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-13
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-03-27
- Letzte Einreichung: 2024-03-13
-
PICASSO PICTURES LIMITED Firmenbeschreibung
- PICASSO PICTURES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06157859. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.03.2007 registriert. PICASSO PICTURES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen JB&RP LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59111" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 13.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 6Th Floor Charlotte Building erreicht werden.
Jetzt sichern PICASSO PICTURES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Picasso Pictures Limited - 6th Floor Charlotte Building, 17 Gresse Street, London, W1T 1QL, Grossbritannien
- 2007-03-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PICASSO PICTURES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-03-19) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2024-03-21) - PSC04
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-18) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-17) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-27) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-21) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-08) - AR01
-
capital-alter-shares-consolidation (2015-01-27) - SH02
-
resolution (2015-01-27) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-14) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-08) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-04-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-cancellation-shares (2013-12-02) - SH06
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-24) - AA
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-11-21) - SH02
-
resolution (2013-12-02) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2013-12-02) - SH03
-
resolution (2013-11-21) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-18) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-secretary-company-with-name (2010-11-02) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-09-10) - AA
-
legacy (2009-04-23) - 363a
-
legacy (2009-04-23) - 288c
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-08-18) - AA
-
legacy (2008-08-06) - 288c
-
legacy (2008-07-18) - 287
-
legacy (2008-05-12) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
certificate-change-of-name-company (2007-05-30) - CERTNM
-
incorporation-company (2007-03-13) - NEWINC
-
legacy (2007-06-25) - 395