-
HF GROUP UK 3 LIMITED - C/O Deloitte Llp PO BOX 500, 2 Hardman Street, Manchester, M60 2AT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06132412
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Deloitte Llp PO BOX 500
- 2 Hardman Street
- Manchester
- M60 2AT C/O Deloitte Llp PO BOX 500, 2 Hardman Street, Manchester, M60 2AT UK
Management
- Geschäftsführung
- MAASSEN, Frank, Dr
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.03.2007
- Gelöscht am:
- 2021-02-28
- SIC/NACE
- 7487
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- HACKREMCO (NO. 2467) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2011-12-31
- Letzte Einreichung: 2010-03-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2011-03-01
-
HF GROUP UK 3 LIMITED Firmenbeschreibung
- HF GROUP UK 3 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06132412. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 01.03.2007 registriert. HF GROUP UK 3 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HACKREMCO (NO. 2467) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "7487" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28/03/2010 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 01.03.2011.Die Firma kann schriftlich über C/o Deloitte Llp Po Box 500 erreicht werden.
Jetzt sichern HF GROUP UK 3 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hf Group Uk 3 Limited - C/O Deloitte Llp PO BOX 500, 2 Hardman Street, Manchester, M60 2AT, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HF GROUP UK 3 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-02-28) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-11-28) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-01-15) - GAZ1
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-11-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-04) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-11-30) - 600
-
restoration-order-of-court (2018-11-14) - AC92
keyboard_arrow_right 2015
-
gazette-dissolved-liquidation (2015-09-09) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2015-06-09) - 4.72
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-11-12) - 4.68
keyboard_arrow_right 2013
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2013-11-08) - 4.68
keyboard_arrow_right 2012
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2012-11-15) - 4.68
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-01-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-02) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-06-20) - TM02
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2011-09-23) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2011-09-23) - 600
-
resolution (2011-09-23) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-27) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-01-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-08) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-03-08) - CH03
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-19) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-07) - 288a
-
legacy (2008-07-07) - 288b
-
legacy (2008-03-14) - 363a
-
legacy (2008-01-07) - 225
-
accounts-with-accounts-type-full (2008-12-29) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
certificate-change-of-name-company (2007-04-02) - CERTNM
-
legacy (2007-04-18) - 288a
-
legacy (2007-04-18) - 288b
-
legacy (2007-04-18) - 225
-
resolution (2007-04-18) - RESOLUTIONS
-
legacy (2007-04-24) - 288b
-
legacy (2007-04-27) - 88(2)R
-
legacy (2007-04-27) - 287
-
legacy (2007-07-26) - 288a
-
legacy (2007-09-11) - 288b
-
legacy (2007-09-14) - 288a
-
incorporation-company (2007-03-01) - NEWINC