-
BLUE GLASS BEDFORD LTD - 29-31 St. Peters Street, Bedford, MK40 2PN, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06117213
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 29-31 St. Peters Street
- Bedford
- MK40 2PN
- England 29-31 St. Peters Street, Bedford, MK40 2PN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- KAVANAGH, Kevin David
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.02.2007
- Gelöscht am:
- 2021-09-07
- SIC/NACE
- 47250
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Patrick Barnes
- Mr Kevin Kavanagh
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- MARSTON THRIFT FOUR LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2019-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-02-20
-
BLUE GLASS BEDFORD LTD Firmenbeschreibung
- BLUE GLASS BEDFORD LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06117213. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.02.2007 registriert. BLUE GLASS BEDFORD LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MARSTON THRIFT FOUR LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47250" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 29/02/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.02.2012.Die Firma kann schriftlich über 29-31 St. Peters Street erreicht werden.
Jetzt sichern BLUE GLASS BEDFORD LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Blue Glass Bedford Ltd - 29-31 St. Peters Street, Bedford, MK40 2PN, England, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLUE GLASS BEDFORD LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-compulsory (2021-09-07) - GAZ2
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2021-01-08) - AA01
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-15) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-07-07) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-07) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-11-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-17) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-02-25) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-25) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-25) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-29) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-11-21) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-11-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-15) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-01) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-31) - AA
-
legacy (2009-04-20) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
certificate-change-of-name-company (2008-02-20) - CERTNM
-
legacy (2008-03-03) - 288a
-
legacy (2008-07-16) - 363a
-
legacy (2008-07-25) - 288b
-
legacy (2008-07-25) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-11-10) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-02-22) - 288a
-
legacy (2007-02-21) - 288a
-
legacy (2007-02-21) - 288b
-
incorporation-company (2007-02-20) - NEWINC