-
MAL REALISATIONS LIMITED - 81 Station Road, Marlow, Bucks, SL7 1NS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06060941
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 81 Station Road
- Marlow
- Bucks
- SL7 1NS 81 Station Road, Marlow, Bucks, SL7 1NS UK
Management
- Geschäftsführung
- LEES, David Franklin
- LEES, Paul Henry
- RAI, Suresh Vikra Chandra
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.01.2007
- Gelöscht am:
- 2022-07-04
- SIC/NACE
- 25990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Franklin Lees
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- MODE-AL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-01-31
- Letzte Einreichung: 2017-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-01-14
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
-
MAL REALISATIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- MAL REALISATIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06060941. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 22.01.2007 registriert. MAL REALISATIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MODE-AL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 81 Station Road erreicht werden.
Jetzt sichern MAL REALISATIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mal Realisations Limited - 81 Station Road, Marlow, Bucks, SL7 1NS, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MAL REALISATIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-09-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2019-01-11) - AM02
-
liquidation-in-administration-proposals (2019-01-18) - AM03
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2019-02-12) - AM06
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2019-02-12) - AM07
-
resolution (2019-03-15) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-07-31) - 600
-
resolution (2019-04-25) - RESOLUTIONS
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2019-07-15) - AM22
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-07-16) - AM10
-
change-of-name-notice (2019-03-18) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-11) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-14) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-12-11) - AM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-09-13) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-04-27) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-25) - AD01
-
capital-alter-shares-subdivision (2011-04-28) - SH02
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-04-19) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-19) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-04-15) - SH01
-
resolution (2011-04-14) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-03) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-09-04) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-02-05) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-12) - 363a
-
legacy (2009-06-26) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-01) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-11-06) - AA
-
legacy (2008-09-15) - 225
-
legacy (2008-07-21) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-09-07) - 395
-
legacy (2007-08-29) - 288b
-
legacy (2007-08-29) - 288a
-
certificate-change-of-name-company (2007-05-31) - CERTNM
-
legacy (2007-03-22) - 288a
-
legacy (2007-02-17) - 288b
-
legacy (2007-02-15) - 288a
-
incorporation-company (2007-01-22) - NEWINC