-
LONDON & GENERAL PACKAGING LTD - Nalco Head Office, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05990129
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Nalco Head Office
- Winnington Avenue
- Northwich
- Cheshire
- CW8 4DX
- United Kingdom Nalco Head Office, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire, CW8 4DX, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BILLETTE DE VILLEMEUR, Eric
- HEY, Paul
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.11.2006
- Gelöscht am:
- 2022-01-18
- SIC/NACE
- 82920
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Ecolab (Uk) Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-08-31
- Letzte Einreichung: 2020-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-21
- Letzte Einreichung: 2020-11-07
-
LONDON & GENERAL PACKAGING LTD Firmenbeschreibung
- LONDON & GENERAL PACKAGING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05990129. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 07.11.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82920" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Nalco Head Office erreicht werden.
Jetzt sichern LONDON & GENERAL PACKAGING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: London & General Packaging Ltd - Nalco Head Office, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LONDON & GENERAL PACKAGING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
gazette-dissolved-voluntary (2022-01-18) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-notice-voluntary (2021-11-02) - GAZ1(A)
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-09-04) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-10-26) - DS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-11-05) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-02) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-11-14) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-11) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-10) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-01-10) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-11) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-19) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-15) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-05) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-23) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-16) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-08) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-10) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-17) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-09) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-01-21) - 288b
-
legacy (2009-01-22) - 287
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-03-10) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-10) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-10) - AR01
-
legacy (2009-04-04) - 88(2)
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-18) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-04-16) - AA
-
legacy (2008-01-17) - 363s
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-12) - 88(2)R
-
legacy (2006-12-12) - 288b
-
legacy (2006-12-12) - 288a
-
incorporation-company (2006-11-07) - NEWINC