-
LIV2RACE LTD - 3, Newhouse Business Centre, Old Crawley Road, Horsham, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05986231
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3
- Newhouse Business Centre
- Old Crawley Road
- Horsham
- West Sussex
- RH12 4RU
- England 3, Newhouse Business Centre, Old Crawley Road, Horsham, West Sussex, RH12 4RU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BALL, Timothy James
- Prokuristen
- BALL, Holly Louise Guilford
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.11.2006
- Alter der Firma 2006-11-02 17 Jahre
- SIC/NACE
- 28110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Timothy James Ball
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- BRD HOLDINGS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-02
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-16
- Letzte Einreichung: 2020-11-02
-
LIV2RACE LTD Firmenbeschreibung
- LIV2RACE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05986231. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.11.2006 registriert. LIV2RACE LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BRD HOLDINGS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "28110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 02.11.2012.Die Firma kann schriftlich über 3 erreicht werden.
Jetzt sichern LIV2RACE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Liv2Race Ltd - 3, Newhouse Business Centre, Old Crawley Road, Horsham, Grossbritannien
- 2006-11-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LIV2RACE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-04) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-01-24) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-29) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-01-24) - PSC01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-04) - CS01
-
resolution (2019-10-02) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-25) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-09-25) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-26) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-18) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-11-18) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-04) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-21) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-29) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-02) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-11-02) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-06) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-24) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-02) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-03) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-08-01) - AA
-
legacy (2008-08-01) - 225
-
legacy (2008-01-24) - 88(2)R
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-22) - 288a
-
legacy (2007-11-23) - 363a
-
legacy (2007-11-23) - 288a
-
legacy (2007-11-26) - 288c
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-11-02) - NEWINC