-
4U WI-FI LIMITED - Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05956859
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Central Square 8th Floor
- 29 Wellington Street
- Leeds
- West Yorkshire
- LS1 4DL Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 4DL UK
Management
- Geschäftsführung
- KASSLER, David Nicholas
- LLOYD, Steven
- MORRIS, John Edward
- Prokuristen
- LLOYD, Steven
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.10.2006
- Gelöscht am:
- 2020-03-31
- SIC/NACE
- 61200
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- PHONES FOR YOU LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-09-30
- Letzte Einreichung: 2012-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-05
-
4U WI-FI LIMITED Firmenbeschreibung
- 4U WI-FI LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05956859. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 05.10.2006 registriert. 4U WI-FI LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PHONES FOR YOU LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61200" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 05.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Central Square 8Th Floor erreicht werden.
Jetzt sichern 4U WI-FI LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 4U Wi-Fi Limited - Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 4U WI-FI LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-03-31) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-11-04) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2019-12-31) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-11-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-11-10) - LIQ03
-
liquidation-miscellaneous (2017-01-30) - LIQ MISC
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-12-21) - 600
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2016-12-21) - LIQ MISC OC
-
liquidation-voluntary-cease-to-act-as-liquidator (2016-12-21) - 4.40
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-11-11) - 4.68
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-14) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2015-04-26) - 2.24B
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2015-09-02) - 2.34B
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-09-22) - 600
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2015-09-23) - 2.24B
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2014-11-18) - 2.16B
-
liquidation-in-administration-proposals (2014-11-13) - 2.17B
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-01) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2014-09-29) - 2.12B
-
termination-director-company-with-name (2014-01-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-13) - AP01
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2014-12-05) - 2.23B
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-01) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-01) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2011-10-12) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2011-10-12) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-09-26) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2011-06-15) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-06-15) - AP03
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-09-24) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-10-29) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2009-10-29) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-10) - 363a
-
legacy (2008-10-10) - 353
-
legacy (2008-10-10) - 287
-
legacy (2008-10-10) - 190
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-07-22) - AA
-
legacy (2008-03-06) - 287
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-30) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-10-30) - 225
-
certificate-change-of-name-company (2006-10-24) - CERTNM
-
legacy (2006-10-05) - 288b
-
incorporation-company (2006-10-05) - NEWINC