-
EUROPEAN CARGO SYSTEMS LIMITED - The Chancery, 58 Spring Gardens, Manchester, M2 1EW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05890930
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Chancery
- 58 Spring Gardens
- Manchester
- M2 1EW The Chancery, 58 Spring Gardens, Manchester, M2 1EW UK
Management
- Geschäftsführung
- SCHOFIELD, Simon
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.07.2006
- Gelöscht am:
- 2022-01-12
- SIC/NACE
- 49410
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Schofield
- Mr Simon Schofield
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- WILD PITCH LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-08-14
- Letzte Einreichung: 2017-07-31
-
EUROPEAN CARGO SYSTEMS LIMITED Firmenbeschreibung
- EUROPEAN CARGO SYSTEMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05890930. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 31.07.2006 registriert. EUROPEAN CARGO SYSTEMS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WILD PITCH LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "49410" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Chancery erreicht werden.
Jetzt sichern EUROPEAN CARGO SYSTEMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: European Cargo Systems Limited - The Chancery, 58 Spring Gardens, Manchester, M2 1EW, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EUROPEAN CARGO SYSTEMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-10-12) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-04-19) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-24) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-03-08) - 600
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2019-02-14) - AM22
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-in-administration-progress-report (2018-09-13) - AM10
-
liquidation-in-administration-proposals (2018-04-24) - AM03
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2018-04-24) - AM06
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2018-04-16) - AM02
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2018-04-16) - AM06
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-03-27) - AM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-15) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-08-15) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-09) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-11-12) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-22) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-01) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-22) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-03) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-08-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-05-25) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-01) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-04-03) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-05-15) - 225
-
legacy (2008-09-25) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-09-20) - 363a
-
legacy (2007-04-25) - 287
keyboard_arrow_right 2006
-
memorandum-articles (2006-10-04) - MEM/ARTS
-
certificate-change-of-name-company (2006-09-29) - CERTNM
-
legacy (2006-09-23) - 395
-
legacy (2006-09-01) - 288a
-
legacy (2006-08-21) - 288b
-
legacy (2006-08-21) - 288a
-
legacy (2006-08-21) - 287
-
incorporation-company (2006-07-31) - NEWINC