-
DEBT CONFIDENTIAL LIMITED - Greystones, Winsford, Minehead, TA24 7JQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05875726
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Greystones
- Winsford
- Minehead
- TA24 7JQ
- England Greystones, Winsford, Minehead, TA24 7JQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MERRITT, Paul Cyril
- Prokuristen
- PICKARD, Stephen Martin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.07.2006
- Alter der Firma 2006-07-13 17 Jahre
- SIC/NACE
- 64999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Lianne Estelle Firth
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PAYPLAN (IVA) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-07-13
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-07-27
- Letzte Einreichung: 2019-07-13
-
DEBT CONFIDENTIAL LIMITED Firmenbeschreibung
- DEBT CONFIDENTIAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05875726. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.07.2006 registriert. DEBT CONFIDENTIAL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PAYPLAN (IVA) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 13.07.2013.Die Firma kann schriftlich über Greystones erreicht werden.
Jetzt sichern DEBT CONFIDENTIAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Debt Confidential Limited - Greystones, Winsford, Minehead, TA24 7JQ, Grossbritannien
- 2006-07-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DEBT CONFIDENTIAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-27) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-27) - PSC07
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-27) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-20) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-03) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-16) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-16) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-21) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-15) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-27) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-15) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-09-04) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2013-09-04) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-30) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-24) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-01) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-07-01) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2013-05-20) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-04-16) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2013-04-11) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-05-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-10-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-09-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-13) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-09-24) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-10-01) - AA
-
legacy (2009-07-15) - 363a
-
legacy (2009-07-15) - 288c
-
certificate-change-of-name-company (2009-06-10) - CERTNM
-
legacy (2009-06-08) - 288a
-
legacy (2009-06-03) - 288c
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-08-20) - 287
-
legacy (2008-07-14) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-05-08) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-15) - 225
-
legacy (2007-08-20) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-07-13) - NEWINC