-
EHC OAKLAND HOUSE LIMITED - Bollin House, Riverside Park, Bollin Link, Wilmslow, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05847763
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bollin House, Riverside Park
- Bollin Link
- Wilmslow
- Cheshire
- SK9 1DP Bollin House, Riverside Park, Bollin Link, Wilmslow, Cheshire, SK9 1DP UK
Management
- Geschäftsführung
- ALEXANDER, Helen Jane
- LLOYD, Lyndsey Ann
- MOODLEY, Devan
- WARD, Dale
- WELLS, Matthew Donald
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.06.2006
- Alter der Firma 2006-06-15 17 Jahre
- SIC/NACE
- 86900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Equilibrium Healthcare Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-06-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-29
- Letzte Einreichung: 2020-06-15
-
EHC OAKLAND HOUSE LIMITED Firmenbeschreibung
- EHC OAKLAND HOUSE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05847763. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.06.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86900" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.06.2013.Die Firma kann schriftlich über Bollin House, Riverside Park erreicht werden.
Jetzt sichern EHC OAKLAND HOUSE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ehc Oakland House Limited - Bollin House, Riverside Park, Bollin Link, Wilmslow, Cheshire, Grossbritannien
- 2006-06-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EHC OAKLAND HOUSE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-25) - TM01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2020-02-25) - AP02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-25) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-15) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-12-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-19) - CS01
-
second-filing-of-director-appointment-with-name (2018-05-10) - RP04AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-04-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-04-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-12-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-16) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-09-29) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-06-12) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-07-31) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-secretary-company-with-name (2012-11-13) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2012-11-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-21) - AR01
-
move-registers-to-registered-office-company (2012-06-21) - AD04
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-03-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-03-16) - AA
-
change-sail-address-company (2010-06-29) - AD02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-29) - AR01
-
move-registers-to-sail-company (2010-06-29) - AD03
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-06-25) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-small (2008-12-16) - AA
-
legacy (2008-07-01) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-small (2008-05-02) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-01-12) - 88(2)R
-
legacy (2007-07-13) - 363a
-
statement-of-affairs (2007-01-12) - SA
keyboard_arrow_right 2006
-
resolution (2006-12-21) - RESOLUTIONS
-
legacy (2006-12-20) - 155(6)a
-
resolution (2006-12-20) - RESOLUTIONS
-
legacy (2006-12-19) - 395
-
legacy (2006-09-26) - 287
-
legacy (2006-07-06) - 288b
-
legacy (2006-07-06) - 288a
-
incorporation-company (2006-06-15) - NEWINC