-
BENTLEY HOUSE TRUSTEES LIMITED - 40, Stanley Road, Stourbridge, DY8 2DL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05847132
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 40
- Stanley Road
- Stourbridge
- DY8 2DL
- England 40, Stanley Road, Stourbridge, DY8 2DL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CROOKS, John Cutter
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.06.2006
- Alter der Firma 2006-06-15 17 Jahre
- SIC/NACE
- 65300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr. John Cutter Crooks
- Mr John Cutter Crooks
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-29
- Letzte Einreichung: 2020-06-15
-
BENTLEY HOUSE TRUSTEES LIMITED Firmenbeschreibung
- BENTLEY HOUSE TRUSTEES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05847132. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.06.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "65300" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 40 erreicht werden.
Jetzt sichern BENTLEY HOUSE TRUSTEES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bentley House Trustees Limited - 40, Stanley Road, Stourbridge, DY8 2DL, Grossbritannien
- 2006-06-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BENTLEY HOUSE TRUSTEES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-13) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-08-13) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-29) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-29) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-13) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-12-03) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-03) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-10-31) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-31) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-21) - MR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-09-17) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-09-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-19) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-10-19) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-18) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2011-10-18) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-06) - AR01
-
legacy (2010-08-12) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-11-10) - AA
-
legacy (2009-03-18) - 225
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-23) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-28) - 400
-
legacy (2007-09-28) - 363s
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-06-15) - NEWINC