-
ABSOLUTE CERAMICS LIMITED - Cp House (G7 - F & F), Otterspool Way, Watford, WD25 8HP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05841436
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cp House (G7 - F & F)
- Otterspool Way
- Watford
- WD25 8HP
- England Cp House (G7 - F & F), Otterspool Way, Watford, WD25 8HP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DIXON, Michael George
- KLIGER, Debbie Ann
- KLIGER, Peter David
- MAUGHAN, Richard James
- Prokuristen
- KLIGER, Peter David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.06.2006
- Alter der Firma 2006-06-08 18 Jahre
- SIC/NACE
- 47789
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Peter David Kliger
- Mrs Debbie Ann Kliger
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-08
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-22
- Letzte Einreichung: 2020-06-08
-
ABSOLUTE CERAMICS LIMITED Firmenbeschreibung
- ABSOLUTE CERAMICS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05841436. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.06.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47789" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Cp House (G7 - F & F) erreicht werden.
Jetzt sichern ABSOLUTE CERAMICS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Absolute Ceramics Limited - Cp House (G7 - F & F), Otterspool Way, Watford, WD25 8HP, Grossbritannien
- 2006-06-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ABSOLUTE CERAMICS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-11) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-09) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-26) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-09-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-29) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-09-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-28) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-22) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-22) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-06-22) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-18) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-02) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-11) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-04-21) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-04-21) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-16) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-07-09) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-10-25) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2010-06-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-04-13) - 225
-
legacy (2009-06-12) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-09-03) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-11) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-04-21) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-16) - 363s
-
memorandum-articles (2007-09-11) - MEM/ARTS
-
resolution (2007-09-11) - RESOLUTIONS
-
legacy (2007-06-13) - 288c
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-06-08) - NEWINC