-
J K CARE LIMITED - 108 Fairmile Lane, Cobham, Surrey, KT11 2BX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05840776
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 108 Fairmile Lane
- Cobham
- Surrey
- KT11 2BX 108 Fairmile Lane, Cobham, Surrey, KT11 2BX UK
Management
- Geschäftsführung
- KANESHANATHAN, Janahan
- KANESHANATHAN, Karthika
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.06.2006
- Alter der Firma 2006-06-08 17 Jahre
- SIC/NACE
- 85100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Karthika Kaneshanathan
- Mrs Karthika Kaneshanathan
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-06-30
- Letzte Einreichung: 2021-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-06-22
- Letzte Einreichung: 2022-06-08
-
J K CARE LIMITED Firmenbeschreibung
- J K CARE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05840776. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.06.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 108 Fairmile Lane erreicht werden.
Jetzt sichern J K CARE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: J K Care Limited - 108 Fairmile Lane, Cobham, Surrey, KT11 2BX, Grossbritannien
- 2006-06-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu J K CARE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
resolution (2023-04-08) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-29) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-09-09) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-08) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-08-31) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-24) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-30) - AA
-
accounts-amended-with-made-up-date (2014-01-07) - AAMD
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-secretary-company-with-name (2012-11-07) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-07) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-07) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-25) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2010-03-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-06-01) - AA
-
legacy (2009-09-15) - 288c
-
legacy (2009-09-15) - 288b
-
legacy (2009-09-15) - 287
-
legacy (2009-09-15) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-06-10) - 363a
-
legacy (2008-06-10) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-04-18) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-09) - 363a
-
legacy (2007-03-24) - 395
-
legacy (2007-01-23) - 395
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-06-08) - NEWINC