-
ARCHITEN LANDRELL ASSOCIATES LIMITED - Suite 1, Goldfields House, 18a Gold Tops, Newport, South Wales, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05747925
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 1, Goldfields House
- 18a Gold Tops
- Newport
- South Wales
- NP20 4PH Suite 1, Goldfields House, 18a Gold Tops, Newport, South Wales, NP20 4PH UK
Management
- Geschäftsführung
- MURRAY, Laurence
- ROWELL, Christopher Lancelot
- Prokuristen
- MURRAY, Laurence
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.03.2006
- Gelöscht am:
- 2020-07-29
- SIC/NACE
- 43999
Landes-Besonderheiten
- Firmenname (in Englisch)
- Architen Landrell Associates Limited
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- RDP 29 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-01-31
- Letzte Einreichung: 2014-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-20
-
ARCHITEN LANDRELL ASSOCIATES LIMITED Firmenbeschreibung
- ARCHITEN LANDRELL ASSOCIATES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05747925. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.03.2006 registriert. ARCHITEN LANDRELL ASSOCIATES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen RDP 29 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.03.2012.Die Firma kann schriftlich über Suite 1, Goldfields House erreicht werden.
Jetzt sichern ARCHITEN LANDRELL ASSOCIATES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Architen Landrell Associates Limited - Suite 1, Goldfields House, 18a Gold Tops, Newport, South Wales, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ARCHITEN LANDRELL ASSOCIATES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-07-29) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-01-02) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-04-29) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-28) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-03-02) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-03-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-02-08) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-disclaimer-notice (2016-01-06) - F10.2
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-12) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-03) - AA
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-12-30) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-12-30) - 4.20
-
resolution (2015-12-30) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-05-12) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-10) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-11-21) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-05-13) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-05-13) - CH03
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-13) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-25) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-06-22) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-05-26) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-05-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-11-17) - AA
-
legacy (2009-04-15) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-01-16) - AA
-
legacy (2008-03-18) - 288b
-
legacy (2008-05-06) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-09-11) - AA
-
legacy (2008-06-28) - 395
-
legacy (2008-05-12) - 88(2)
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-03-15) - 225
-
legacy (2007-04-20) - 88(2)R
-
legacy (2007-12-10) - 88(2)R
-
legacy (2007-04-20) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-11-29) - 288a
-
legacy (2006-04-26) - 287
-
legacy (2006-04-25) - 288a
-
legacy (2006-04-19) - 288a
-
legacy (2006-04-19) - 288b
-
certificate-change-of-name-company (2006-04-07) - CERTNM
-
incorporation-company (2006-03-20) - NEWINC