-
CONTINENTAL HYDRAULICS UK LIMITED - Unit 35 Old Mills Industrial Estate, Paulton, Bristol, BS39 7SU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05711867
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 35 Old Mills Industrial Estate
- Paulton
- Bristol
- BS39 7SU
- England Unit 35 Old Mills Industrial Estate, Paulton, Bristol, BS39 7SU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- STARR, Amy
- STARR, Oliver
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.02.2006
- Alter der Firma 2006-02-16 18 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Oliver Lawrence Starr
- Mrs Amy Elizabeth Starr
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-14
- Letzte Einreichung: 2021-01-31
-
CONTINENTAL HYDRAULICS UK LIMITED Firmenbeschreibung
- CONTINENTAL HYDRAULICS UK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05711867. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.02.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Unit 35 Old Mills Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern CONTINENTAL HYDRAULICS UK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Continental Hydraulics Uk Limited - Unit 35 Old Mills Industrial Estate, Paulton, Bristol, BS39 7SU, Grossbritannien
- 2006-02-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CONTINENTAL HYDRAULICS UK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-04-02) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-02-17) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-06-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-12-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-10) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-03) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-24) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-07-24) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2014-08-12) - RP04
-
capital-allotment-shares (2014-06-04) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-12-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-12-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-12-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-01-25) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-14) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-12-10) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-02-26) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-01-14) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-02-18) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2007-12-18) - AA
-
legacy (2007-03-01) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-05-17) - 288a
-
incorporation-company (2006-02-16) - NEWINC
-
legacy (2006-02-16) - 288b
-
legacy (2006-05-17) - 225