-
NUXLEY HOMES (SOUTH EAST) LIMITED - 5 North Street, Hailsham, East Sussex, BN27 1DQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05644921
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 North Street
- Hailsham
- East Sussex
- BN27 1DQ 5 North Street, Hailsham, East Sussex, BN27 1DQ UK
Management
- Geschäftsführung
- BECK, Stephen Archer
- JOLLY, Kenneth
- Prokuristen
- JOLLY, Kenneth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.12.2005
- Alter der Firma 2005-12-05 18 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kenneth Jolly
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-23
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-16
- Letzte Einreichung: 2019-12-05
-
NUXLEY HOMES (SOUTH EAST) LIMITED Firmenbeschreibung
- NUXLEY HOMES (SOUTH EAST) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05644921. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.12.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 05.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 5 North Street erreicht werden.
Jetzt sichern NUXLEY HOMES (SOUTH EAST) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nuxley Homes (South East) Limited - 5 North Street, Hailsham, East Sussex, BN27 1DQ, Grossbritannien
- 2005-12-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NUXLEY HOMES (SOUTH EAST) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-compulsory (2021-04-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-08) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-12-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-05) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-12-05) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-10-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2019-10-03) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-11-12) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-15) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-04-24) - DISS40
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-09) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2017-11-28) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-01-10) - DISS40
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-12-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-24) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-12-04) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-12-04) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-01) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-17) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-11) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-11) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-03-17) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-06) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-18) - CH01
-
termination-director-company-with-name (2009-12-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-12-15) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-27) - AA
-
legacy (2009-08-04) - 288b
-
accounts-amended-with-made-up-date (2009-04-22) - AAMD
-
legacy (2009-02-12) - 363a
-
legacy (2009-02-09) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-10-29) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-02-13) - 363a
-
legacy (2007-03-31) - 395
-
legacy (2007-04-12) - 395
-
legacy (2007-09-01) - 395
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2007-10-04) - AA
-
legacy (2007-07-30) - 288c
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-03-22) - 88(2)R
-
legacy (2006-02-21) - 88(2)R
-
legacy (2006-01-17) - 287
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-12-20) - 288a
-
legacy (2005-12-20) - 288b
-
incorporation-company (2005-12-05) - NEWINC