-
SULLIVAN INNS LIMITED - GRANT THORNTON UK LLP, 30 Finsbury Square, London, EC2P 1AG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05620997
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- GRANT THORNTON UK LLP
- 30 Finsbury Square
- London
- EC2P 1AG GRANT THORNTON UK LLP, 30 Finsbury Square, London, EC2P 1AG UK
Management
- Geschäftsführung
- MANN, Michael
- O'SULLIVAN, Margaret Majella
- O'SULLIVAN, Padraic
- Prokuristen
- HALL, Paul Nunnerley
- OSULLIVAN, Alison
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.11.2005
- Alter der Firma 2005-11-14 18 Jahre
- SIC/NACE
- 5530
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2009-10-31
- Letzte Einreichung: 2007-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2009-11-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-11-28
- Letzte Einreichung:
-
SULLIVAN INNS LIMITED Firmenbeschreibung
- SULLIVAN INNS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05620997. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.11.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "5530" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 2 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2007 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.11.2009.Die Firma kann schriftlich über Grant Thornton Uk Llp erreicht werden.
Jetzt sichern SULLIVAN INNS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sullivan Inns Limited - GRANT THORNTON UK LLP, 30 Finsbury Square, London, EC2P 1AG, Grossbritannien
- 2005-11-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SULLIVAN INNS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-10-07) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-08-10) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-09-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-12-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-06-14) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-08-07) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2014-06-24) - 600
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2014-07-04) - 2.24B
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2014-08-20) - 2.24B
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2014-05-30) - 2.34B
-
liquidation-voluntary-removal-liquidator (2014-10-23) - 4.38
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-24) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2014-11-07) - 600
keyboard_arrow_right 2013
-
liquidation-in-administration-amended-certificate-of-constitution-creditors-committee (2013-06-21) - 2.26B
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2013-07-12) - 2.31B
keyboard_arrow_right 2012
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2012-06-01) - 2.31B
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2012-12-11) - 2.31B
keyboard_arrow_right 2011
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2011-11-29) - 2.31B
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2011-06-03) - 2.31B
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2011-06-03) - 2.24B
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2011-02-16) - 2.23B
-
liquidation-in-administration-revised-proposals (2011-02-11) - 2.22B
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2011-01-12) - 2.24B
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-24) - AD01
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2010-08-20) - 2.23B
-
liquidation-in-administration-proposals (2010-08-04) - 2.17B
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2010-06-08) - 2.12B
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-10) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-10) - CH01
-
gazette-notice-compulsary (2010-06-08) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-04) - AA
-
legacy (2009-06-26) - 287
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-01-14) - 288a
-
legacy (2008-02-20) - 395
-
legacy (2008-02-16) - 403a
-
legacy (2008-12-01) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-16) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-10-05) - AA
-
legacy (2007-09-17) - 88(2)R
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-01-19) - 288a
-
legacy (2006-03-16) - 395
-
legacy (2006-05-19) - 395
-
legacy (2006-12-12) - 363s
-
legacy (2006-12-04) - 225
-
legacy (2006-12-29) - 88(2)R
-
legacy (2006-06-13) - 88(2)R
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-12-07) - 288a
-
legacy (2005-12-06) - 288a
-
resolution (2005-11-24) - RESOLUTIONS
-
legacy (2005-11-16) - 288b
-
incorporation-company (2005-11-14) - NEWINC