-
WHOLESALE SOLUTIONS LIMITED - 81 Station Road, Marlow, Bucks, SL7 1NS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05448425
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 81 Station Road
- Marlow
- Bucks
- SL7 1NS 81 Station Road, Marlow, Bucks, SL7 1NS UK
Management
- Geschäftsführung
- O'REILLY, James
- Prokuristen
- ATTWOOD, Gary John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.05.2005
- Gelöscht am:
- 2020-08-21
- SIC/NACE
- 47910
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr James William O'Reilly
- Mr Alun Attwood
- Mr Alun Attwood
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-02-28
- Letzte Einreichung: 2016-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-10
-
WHOLESALE SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- WHOLESALE SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05448425. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.05.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47910" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 81 Station Road erreicht werden.
Jetzt sichern WHOLESALE SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Wholesale Solutions Limited - 81 Station Road, Marlow, Bucks, SL7 1NS, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WHOLESALE SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-08-21) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-05-21) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-08-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-26) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-06-22) - 600
-
resolution (2018-06-22) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-06-22) - LIQ02
-
resolution (2018-06-08) - RESOLUTIONS
-
gazette-notice-compulsory (2018-05-01) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-07) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-18) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-16) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-17) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-16) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-06-07) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-04) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2014-06-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-29) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-05-29) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-05-29) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-12-10) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-12-07) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-14) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-22) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-06-22) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-06-22) - CH03
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-03) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-08-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-28) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-05-01) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2009-05-02) - DISS40
-
legacy (2009-05-01) - 363a
-
legacy (2009-07-23) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-27) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-05-05) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
gazette-notice-compulsary (2008-12-30) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-06-11) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-03-19) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-01-20) - 288b
-
legacy (2006-01-20) - 288a
-
legacy (2006-02-22) - 288a
-
legacy (2006-02-22) - 287
-
legacy (2006-02-22) - 288b
-
legacy (2006-05-30) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-05-11) - 288a
-
legacy (2005-05-11) - 287
-
legacy (2005-05-11) - 288b
-
incorporation-company (2005-05-10) - NEWINC