-
HERRINGTON GATE FURNITURE LTD - 1 St. James Gate, Newcastle Upon Tyne, NE1 4AD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05379161
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 St. James Gate
- Newcastle Upon Tyne
- NE1 4AD 1 St. James Gate, Newcastle Upon Tyne, NE1 4AD UK
Management
- Geschäftsführung
- STEPHENSON, Ashley Monique
- STEPHENSON, Michael Jason
- Prokuristen
- STEPHENSON, Ashley Monique
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.03.2005
- Gelöscht am:
- 2020-07-30
- SIC/NACE
- 41100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- 47 MS LAND AND PROPERTY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-07-31
- Letzte Einreichung: 2013-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-01
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-03-15
- Letzte Einreichung:
-
HERRINGTON GATE FURNITURE LTD Firmenbeschreibung
- HERRINGTON GATE FURNITURE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05379161. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 01.03.2005 registriert. HERRINGTON GATE FURNITURE LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen 47 MS LAND AND PROPERTY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 01.03.2013.Die Firma kann schriftlich über 1 St. James Gate erreicht werden.
Jetzt sichern HERRINGTON GATE FURNITURE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Herrington Gate Furniture Ltd - 1 St. James Gate, Newcastle Upon Tyne, NE1 4AD, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HERRINGTON GATE FURNITURE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-04-30) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-01-05) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-12-31) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-12-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-12-22) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-12-22) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-11-29) - 4.68
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2016-01-22) - LIQ MISC OC
-
liquidation-voluntary-cease-to-act-as-liquidator (2016-01-22) - 4.40
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-01-22) - 600
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-11-11) - 4.68
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-20) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-06) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2014-11-05) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2014-11-05) - 4.20
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-07-22) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-05) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2012-11-05) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-04) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-29) - AR01
-
move-registers-to-sail-company (2010-04-29) - AD03
-
change-sail-address-company (2010-04-29) - AD02
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-31) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2009-07-28) - DISS40
-
legacy (2009-07-27) - 363a
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2009-07-01) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2009-06-30) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-07-29) - AA
-
legacy (2008-03-31) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-05-03) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-09-27) - AA
-
legacy (2007-09-13) - 88(2)R
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2006-10-20) - AA
-
legacy (2006-10-20) - 225
-
legacy (2006-04-12) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-03-24) - 288b
-
legacy (2005-03-24) - 288a
-
legacy (2005-03-24) - 287
-
incorporation-company (2005-03-01) - NEWINC