-
STONEMAN STAINLESS HAULAGE LIMITED - Griffins Tavistock House South, Tavistock Square, London, WC1H 9LG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05351496
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Griffins Tavistock House South
- Tavistock Square
- London
- WC1H 9LG Griffins Tavistock House South, Tavistock Square, London, WC1H 9LG UK
Management
- Geschäftsführung
- STONEMAN, Robert James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.02.2005
- Gelöscht am:
- 2020-02-27
- SIC/NACE
- 6024
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2012-11-30
- Letzte Einreichung: 2011-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2011-02-03
-
STONEMAN STAINLESS HAULAGE LIMITED Firmenbeschreibung
- STONEMAN STAINLESS HAULAGE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05351496. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 03.02.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "6024" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28/02/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.02.2011.Die Firma kann schriftlich über Griffins Tavistock House South erreicht werden.
Jetzt sichern STONEMAN STAINLESS HAULAGE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Stoneman Stainless Haulage Limited - Griffins Tavistock House South, Tavistock Square, London, WC1H 9LG, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STONEMAN STAINLESS HAULAGE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-02-27) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-09-05) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2019-11-27) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-09-05) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-09-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-07-08) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-08-18) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-07-22) - 4.68
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2014-02-18) - LIQ MISC OC
-
liquidation-miscellaneous (2014-02-18) - LIQ MISC
-
liquidation-voluntary-cease-to-act-as-liquidator (2014-02-18) - 4.40
keyboard_arrow_right 2013
-
liquidation-disclaimer-notice (2013-01-21) - F10.2
-
liquidation-voluntary-cease-to-act-as-liquidator (2013-04-03) - 4.40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-11) - AD01
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2013-04-12) - LIQ MISC OC
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2013-07-24) - 4.68
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2013-04-12) - 600
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-10) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2012-07-10) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2012-07-10) - 600
-
resolution (2012-07-10) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-05) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2012-07-04) - 600
-
resolution (2012-07-04) - RESOLUTIONS
-
gazette-notice-compulsary (2012-06-05) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-02-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-secretary-company-with-name (2011-08-22) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-02-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-30) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date (2010-03-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-08-01) - 395
-
legacy (2009-03-16) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-02-13) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-02-26) - 287
-
legacy (2008-02-26) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-08-05) - AA
-
legacy (2008-03-04) - 287
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-04-13) - 363s
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-12-15) - AA
-
legacy (2006-03-02) - 363s
-
legacy (2006-01-20) - 395
keyboard_arrow_right 2005
-
resolution (2005-03-09) - RESOLUTIONS
-
legacy (2005-02-16) - 288b
-
legacy (2005-02-09) - 288b
-
incorporation-company (2005-02-03) - NEWINC