-
THE SPECTACLE OUTLET LIMITED - Unit 8b, Marina Court, Castle Street, Hull, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05255110
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 8b
- Marina Court
- Castle Street
- Hull
- HU1 1TJ Unit 8b, Marina Court, Castle Street, Hull, HU1 1TJ UK
Management
- Geschäftsführung
- BAILEY, Anne-Marie
- BAILEY, David Gregory
- SILBY, Keith
- Prokuristen
- SILBY, Glenda Kay
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.10.2004
- Gelöscht am:
- 2020-10-18
- SIC/NACE
- 47789
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Keith Silby
- Mr Keith Silby
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-10-31
- Letzte Einreichung: 2018-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-13
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-12-16
- Letzte Einreichung: 2018-12-02
-
THE SPECTACLE OUTLET LIMITED Firmenbeschreibung
- THE SPECTACLE OUTLET LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05255110. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.10.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47789" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 13.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Unit 8B erreicht werden.
Jetzt sichern THE SPECTACLE OUTLET LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Spectacle Outlet Limited - Unit 8b, Marina Court, Castle Street, Hull, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE SPECTACLE OUTLET LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-07-18) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-06-07) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-06-07) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-19) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-06-07) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-08) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-04) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-03) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-09) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-22) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-12-18) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-30) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-12-18) - CH03
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-12-18) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-12-19) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-09) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-29) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-05) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-05) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-03-22) - AD01
-
capital-allotment-shares (2011-10-05) - SH01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-09) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-11-27) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-28) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-23) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-08-01) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-01-05) - 363s
-
legacy (2006-07-27) - 225
-
legacy (2006-12-05) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-12-23) - 395
-
legacy (2004-12-01) - 288a
-
legacy (2004-12-01) - 287
-
legacy (2004-10-18) - 287
-
legacy (2004-10-18) - 288b
-
incorporation-company (2004-10-11) - NEWINC