-
JTB ELECTRICAL SERVICES LIMITED - Unit 8 Mill House Offices, 108 Commercial Road Totton, Southampton, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05179049
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 8 Mill House Offices
- 108 Commercial Road Totton
- Southampton
- Hampshire
- SO40 3AE Unit 8 Mill House Offices, 108 Commercial Road Totton, Southampton, Hampshire, SO40 3AE UK
Management
- Geschäftsführung
- HARTLEY, James Edward
- Prokuristen
- RANDALL, Claire Nicola
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.07.2004
- Alter der Firma 2004-07-14 20 Jahre
- SIC/NACE
- 43390
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr James Hartley
- Mr James Hartley
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-04-30
- Letzte Einreichung: 2018-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-03
- Letzte Einreichung: 2020-03-20
-
JTB ELECTRICAL SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- JTB ELECTRICAL SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05179049. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.07.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43390" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 8 Mill House Offices erreicht werden.
Jetzt sichern JTB ELECTRICAL SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jtb Electrical Services Limited - Unit 8 Mill House Offices, 108 Commercial Road Totton, Southampton, Hampshire, Grossbritannien
- 2004-07-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JTB ELECTRICAL SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-05-01) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-10) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-22) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-26) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-11-06) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-29) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-20) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-11-16) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-15) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-11-15) - CH03
-
gazette-notice-compulsary (2011-11-08) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-12) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-11-15) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-21) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-02) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-18) - AR01
-
legacy (2009-10-02) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-31) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2009-06-03) - DISS40
-
legacy (2009-06-02) - 363a
-
gazette-notice-compulsary (2009-05-19) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-09-22) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-06-11) - AA
-
legacy (2007-09-14) - 363s
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-01) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-07-26) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-08-03) - 288a
-
legacy (2004-08-03) - 288b
-
legacy (2004-08-03) - 287
-
incorporation-company (2004-07-14) - NEWINC