-
STERLING MATERIALS LIMITED - 2 Snowhill, Birmingham, B4 6GA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05170759
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Snowhill
- Birmingham
- B4 6GA 2 Snowhill, Birmingham, B4 6GA UK
Management
- Geschäftsführung
- BROWNLOW, Andrew
- LAMB, David Peter
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.07.2004
- Alter der Firma 2004-07-05 20 Jahre
- SIC/NACE
- 13923
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Nonwovenn Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- HAMSARD 2746 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-12-31
- Letzte Einreichung: 2017-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-07-19
- Letzte Einreichung: 2017-07-05
-
STERLING MATERIALS LIMITED Firmenbeschreibung
- STERLING MATERIALS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05170759. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.07.2004 registriert. STERLING MATERIALS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HAMSARD 2746 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "13923" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 05.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 2 Snowhill erreicht werden.
Jetzt sichern STERLING MATERIALS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sterling Materials Limited - 2 Snowhill, Birmingham, B4 6GA, Grossbritannien
- 2004-07-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STERLING MATERIALS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-05-27) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-06-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2018-04-19) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-04-19) - 600
-
resolution (2018-04-19) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-04-12) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-14) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-04-28) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-05-03) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-19) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-12) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-14) - AR01
-
capital-return-purchase-own-shares (2014-02-12) - SH03
-
resolution (2014-02-05) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2014-02-05) - SH06
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-11-25) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-18) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-10) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-13) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-07-30) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-07-30) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-22) - AA
-
legacy (2009-07-24) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-02-06) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-31) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-12-18) - AA
-
legacy (2007-09-25) - 395
-
legacy (2007-07-31) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-02-14) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-02-02) - AA
-
legacy (2006-07-31) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-07-29) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-12-06) - 287
-
legacy (2004-12-06) - 288a
-
legacy (2004-11-26) - 288b
-
legacy (2004-11-26) - 288a
-
legacy (2004-11-26) - 225
-
legacy (2004-11-26) - 88(2)R
-
resolution (2004-11-26) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2004-09-29) - CERTNM
-
incorporation-company (2004-07-05) - NEWINC