-
APEX HEALTHCARE CONSULTING LIMITED - Herschel House, 58 Herschel Street, Slough, Berkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05050615
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Herschel House
- 58 Herschel Street
- Slough
- Berkshire
- SL1 1PG Herschel House, 58 Herschel Street, Slough, Berkshire, SL1 1PG UK
Management
- Geschäftsführung
- COTTERELL, David John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.02.2004
- Alter der Firma 2004-02-20 20 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David John Cotterell
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-05
- Letzte Einreichung: 2023-02-20
-
APEX HEALTHCARE CONSULTING LIMITED Firmenbeschreibung
- APEX HEALTHCARE CONSULTING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05050615. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.02.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Herschel House erreicht werden.
Jetzt sichern APEX HEALTHCARE CONSULTING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Apex Healthcare Consulting Limited - Herschel House, 58 Herschel Street, Slough, Berkshire, Grossbritannien
- 2004-02-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu APEX HEALTHCARE CONSULTING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2024-02-28) - TM02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-03-12) - MR04
-
gazette-notice-compulsory (2024-03-12) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2024-03-19) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-03-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-15) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-19) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-12-24) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-07) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-30) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-23) - AA
-
resolution (2010-01-12) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-02-05) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2009-11-06) - AA
-
legacy (2009-03-02) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-03-12) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-01-23) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-03-20) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-02-06) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-03-03) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-03-18) - 225
-
legacy (2005-04-12) - 363s
-
legacy (2005-09-07) - 288b
-
legacy (2005-10-12) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2005-12-28) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-06-04) - 88(2)R
-
legacy (2004-05-26) - 288b
-
legacy (2004-05-26) - 288a
-
incorporation-company (2004-02-20) - NEWINC