-
WILLIAM VERRY (EUROPE) LIMITED - 72 London Road, St Albans, Herts, AL1 1NS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05023685
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 72 London Road
- St Albans
- Herts
- AL1 1NS 72 London Road, St Albans, Herts, AL1 1NS UK
Management
- Geschäftsführung
- GIBSON, John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.01.2004
- Gelöscht am:
- 2020-07-03
- SIC/NACE
- 7499
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- FRONTMILE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2009-10-31
- Letzte Einreichung: 2007-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2009-01-23
-
WILLIAM VERRY (EUROPE) LIMITED Firmenbeschreibung
- WILLIAM VERRY (EUROPE) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05023685. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.01.2004 registriert. WILLIAM VERRY (EUROPE) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FRONTMILE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "7499" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2007 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.01.2009.Die Firma kann schriftlich über 72 London Road erreicht werden.
Jetzt sichern WILLIAM VERRY (EUROPE) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: William Verry (Europe) Limited - 72 London Road, St Albans, Herts, AL1 1NS, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WILLIAM VERRY (EUROPE) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-07-03) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-04-03) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-03-03) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-04-19) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-09-18) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-03-08) - 4.68
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-09-14) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-02-15) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-09-16) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-02-09) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-08-13) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-03-06) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-03-14) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-08-19) - 4.68
keyboard_arrow_right 2013
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2013-02-28) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2013-09-23) - 4.68
keyboard_arrow_right 2012
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2012-08-09) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2012-02-23) - 4.68
keyboard_arrow_right 2011
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2011-09-22) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2011-02-21) - 4.68
keyboard_arrow_right 2010
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2010-02-02) - 2.34B
keyboard_arrow_right 2009
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2009-10-22) - 2.23B
-
liquidation-in-administration-proposals (2009-10-21) - 2.17B
-
liquidation-in-administration-proposals (2009-10-20) - 2.17B
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2009-08-17) - 2.12B
-
legacy (2009-08-14) - 287
-
legacy (2009-01-26) - 363a
-
legacy (2009-05-02) - 288b
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-10-31) - AA
-
legacy (2008-02-05) - 363a
-
legacy (2008-02-05) - 288c
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-12-10) - 288b
-
legacy (2007-12-10) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-11-01) - AA
-
legacy (2007-03-16) - 363a
-
legacy (2007-02-22) - 287
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-01-24) - AA
-
legacy (2006-03-31) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-08-08) - AA
-
legacy (2006-11-24) - 288a
-
legacy (2006-11-15) - 288b
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-02-18) - 363s
-
legacy (2005-01-13) - 225
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-02-25) - 288b
-
legacy (2004-02-20) - 288a
-
legacy (2004-02-20) - 287
-
certificate-change-of-name-company (2004-02-18) - CERTNM
-
incorporation-company (2004-01-23) - NEWINC