-
STRING COMPUTER SYSTEMS LTD - 3 Hardy Close Nelson Court Business Centre, Ashton, Preston, Lancashire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05014752
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3 Hardy Close Nelson Court Business Centre
- Ashton
- Preston
- Lancashire
- PR2 2XP 3 Hardy Close Nelson Court Business Centre, Ashton, Preston, Lancashire, PR2 2XP UK
Management
- Geschäftsführung
- KIVEAL, Paul Phillip
- PICKERING, Stephen Michael
- WRIGHT, Tom
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.01.2004
- Alter der Firma 2004-01-14 20 Jahre
- SIC/NACE
- 62011
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Pen Property Management Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-28
- Letzte Einreichung: 2021-01-14
-
STRING COMPUTER SYSTEMS LTD Firmenbeschreibung
- STRING COMPUTER SYSTEMS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05014752. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.01.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62011" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 3 Hardy Close Nelson Court Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern STRING COMPUTER SYSTEMS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: String Computer Systems Ltd - 3 Hardy Close Nelson Court Business Centre, Ashton, Preston, Lancashire, Grossbritannien
- 2004-01-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STRING COMPUTER SYSTEMS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-08-25) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-02-02) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-03) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-02-03) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-04-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-07-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-07-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-06-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-19) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-03) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-03) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-16) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-20) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-05-13) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-03-02) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-04-17) - AA
-
legacy (2009-02-03) - 363a
-
legacy (2009-01-27) - 288b
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-09-10) - AA
-
legacy (2008-02-01) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-08-17) - AA
-
legacy (2007-01-22) - 363a
-
legacy (2007-01-22) - 288c
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-02-15) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-11-28) - 287
-
legacy (2005-06-28) - 88(2)R
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-06-28) - AA
-
legacy (2005-02-02) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-04-16) - 225
-
legacy (2004-03-02) - 288a
-
legacy (2004-01-24) - 288b
-
legacy (2004-01-19) - 288a
-
incorporation-company (2004-01-14) - NEWINC