-
OXYGEN DIGITAL COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED - C/O GREENFIELD RECOVERY LIMITED, Trinity House 28-30 Blucher St, Birmingham, B1 1QH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04972479
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O GREENFIELD RECOVERY LIMITED
- Trinity House 28-30 Blucher St
- Birmingham
- B1 1QH C/O GREENFIELD RECOVERY LIMITED, Trinity House 28-30 Blucher St, Birmingham, B1 1QH UK
Management
- Geschäftsführung
- HATHAWAY, Stephen Mark
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.11.2003
- Gelöscht am:
- 2020-03-18
- SIC/NACE
- 46520
Eigentumsverhältnisse
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-06-30
- Letzte Einreichung: 2012-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-21
-
OXYGEN DIGITAL COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED Firmenbeschreibung
- OXYGEN DIGITAL COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04972479. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 21.11.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46520" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.11.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Greenfield Recovery Limited erreicht werden.
Jetzt sichern OXYGEN DIGITAL COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Oxygen Digital Communication Technology Limited - C/O GREENFIELD RECOVERY LIMITED, Trinity House 28-30 Blucher St, Birmingham, B1 1QH, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OXYGEN DIGITAL COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-03-18) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-08-30) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2019-12-18) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-10-05) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-10-13) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-31) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-10-18) - 4.68
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-08-24) - 600
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2016-08-24) - LIQ MISC OC
-
liquidation-voluntary-cease-to-act-as-liquidator (2016-08-24) - 4.40
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-09-01) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-10-13) - 4.68
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-17) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-07-19) - MR01
-
resolution (2013-08-12) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2013-08-12) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2013-08-12) - 4.20
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-12-05) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-16) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-06) - AR01
-
legacy (2010-11-09) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-25) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-10-15) - AA01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-08) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-08) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name (2009-12-07) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-09-30) - AA
-
legacy (2009-01-12) - 363a
-
legacy (2009-01-12) - 288c
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-11-28) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-01-10) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-10-01) - AA
-
legacy (2007-01-10) - 363a
-
legacy (2007-12-11) - 288c
-
legacy (2007-12-11) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-10-17) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-12-12) - 363a
-
legacy (2005-01-25) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-12-15) - 288b
-
legacy (2003-12-15) - 288a
-
legacy (2003-12-15) - 287
-
incorporation-company (2003-11-21) - NEWINC