-
LUXURY CABINS LIMITED - Muras Baker Jones 3rd Floor Regent House, Bath Avenue, Wolverhampton, WV1 4EG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04963438
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Muras Baker Jones 3rd Floor Regent House
- Bath Avenue
- Wolverhampton
- WV1 4EG Muras Baker Jones 3rd Floor Regent House, Bath Avenue, Wolverhampton, WV1 4EG UK
Management
- Geschäftsführung
- WITTS, Andrew John
- WITTS, Margaret Rose Julie
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.11.2003
- Alter der Firma 2003-11-13 20 Jahre
- SIC/NACE
- 55209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Andrew John Witts
- Mrs Margaret Rose Julie Witts
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- PAD-LOK PRODUCTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-08-31
- Letzte Einreichung: 2018-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-13
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-11-27
- Letzte Einreichung: 2019-11-13
-
LUXURY CABINS LIMITED Firmenbeschreibung
- LUXURY CABINS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04963438. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.11.2003 registriert. LUXURY CABINS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PAD-LOK PRODUCTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 13.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Muras Baker Jones 3Rd Floor Regent House erreicht werden.
Jetzt sichern LUXURY CABINS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Luxury Cabins Limited - Muras Baker Jones 3rd Floor Regent House, Bath Avenue, Wolverhampton, WV1 4EG, Grossbritannien
- 2003-11-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LUXURY CABINS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-05-20) - LIQ01
-
resolution (2020-05-20) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-05-20) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-06-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-22) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-16) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-11) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-19) - AA
-
change-of-name-notice (2015-10-09) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-10-09) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-07-31) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-11) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-12) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-29) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-15) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-10-13) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-12) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-10-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-10) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2010-01-28) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-08) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-17) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-03-01) - AA
-
legacy (2008-02-21) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-06-11) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-09-18) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-10-05) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-11-18) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-10-13) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-11-15) - 88(2)R
-
legacy (2004-11-09) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-12-08) - 88(2)R
-
legacy (2003-12-08) - 288b
-
legacy (2003-12-08) - 288a
-
incorporation-company (2003-11-13) - NEWINC