-
ST DAVID`S FARM PRACTICE LIMITED - 4, King Square, Bridgwater, Somerset, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04887872
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4
- King Square
- Bridgwater
- Somerset
- TA6 3YF 4, King Square, Bridgwater, Somerset, TA6 3YF UK
Management
- Geschäftsführung
- BEYNON, Alan Huw
- TURNER, Richard George
- Prokuristen
- BEYNON, Alan Huw
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.09.2003
- Gelöscht am:
- 2023-02-07
- SIC/NACE
- 75000
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Alan Huw Beynon
- Mr Richard George Turner
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-09-18
- Letzte Einreichung: 2019-09-04
-
ST DAVID`S FARM PRACTICE LIMITED Firmenbeschreibung
- ST DAVID`S FARM PRACTICE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04887872. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 04.09.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "75000" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 4 erreicht werden.
Jetzt sichern ST DAVID`S FARM PRACTICE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: St David`s Farm Practice Limited - 4, King Square, Bridgwater, Somerset, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ST DAVID`S FARM PRACTICE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-06-27) - AA
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-31) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-10-31) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-31) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2016-11-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-15) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-15) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-07-31) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-10) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-04) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-02-14) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-02-14) - CH03
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-25) - AR01
-
capital-allotment-shares (2011-11-25) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2011-11-25) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-02-10) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-07-28) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-20) - AR01
-
legacy (2009-01-26) - 88(2)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-01-21) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-13) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-01-17) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-09-20) - 363a
-
legacy (2007-03-20) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-03-19) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-01) - 395
-
legacy (2006-10-13) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-02-09) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-07-11) - AA
-
legacy (2005-10-05) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-08-06) - 88(2)R
-
legacy (2004-09-21) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-10-15) - 288b
-
legacy (2003-10-10) - 287
-
legacy (2003-10-10) - 288a
-
incorporation-company (2003-09-04) - NEWINC